ALFACARTERA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 1
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALFACARTERA SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gomez Casals Pascual
VINCULACIONES DE ALFACARTERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFACARTERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Casals Pascual | Presidente | 06/03/2012 | 17/07/2018 |
Gomez Casals Pascual | Consejero | 06/03/2012 | 17/07/2018 |
Gomez Casals Pascual | Consejero | 30/11/2015 | 17/07/2018 |
Gomez Garcia Daniel | Secretario | 06/03/2012 | 17/07/2018 |
Gomez Garcia Daniel | Consejero | 06/03/2012 | 17/07/2018 |
Gomez Garcia Daniel | Consejero Delegado | 06/03/2012 | 17/07/2018 |
Gomez Garcia Daniel | Consejero | 30/11/2015 | 17/07/2018 |
Gomez Garcia Daniel | Consejero Delegado | 30/11/2015 | 17/07/2018 |
Gomez Garcia Soledad | Consejero | 06/03/2012 | 17/07/2018 |
Gomez Garcia Soledad | Consejero | 29/12/2009 | 17/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALFACARTERA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36612 , F 196, S 8, H M 656958, I/A 22 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
- Comunicación de la CNMV manifestando que en fecha 6 de julio de 2018 el Presidente de la misma adoptó la resolución de dar de baja a la entidad "Alfacartera Sa Sicav" del Registro de Sociedad de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de su absorción por "FONMASTER 1" en fecha 29-12-2017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36612 , F 196, S 8, H M 656958, I/A 22 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja social por plazo de SEIS MESES, al extenderse en esta fecha NOTA DE NO OBSTACULOS para la inscripción de la absorción de la sociedad por el Fondo de Inversión "FONMASTER 1 FI" , por analogía con lo establecido en el artículo 231 del Reglamento del Registro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36612 , F 195, S 8, H M 656958, I/A 21-M (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
- C/ SERRANO 1 3º DR (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36612 , F 195, S 8, H M 656958, I/A 21 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39079 , F 107, S 8, H B 78128, I/A 73 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39079 , F 106, S 8, H B 78128, I/A 72 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39079 , F 106, S 8, H B 78128, I/A 71 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
- SUSTITUCION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA, DESIGNANDO A LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, SA (IBERCLEAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39079 , F 106, S 8, H B 78128, I/A 70 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
- Creación de la página web corporativa: CONVOCATORIA DE LA JUNTA EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD GESTORA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39079 , F 106, S 8, H B 78128, I/A 69 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.13.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD GESTORA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39079 , F 106, S 8, H B 78128, I/A 69 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08