CIDEPA-SINCRON SL
Dirección social POLIG INDUSTRIAL POLYSOL 3 - NUMERO 15
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Razón Social CIDEPA-SINCRON SL
CIF B91535914
Capital Social 2296694.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Nombres Anteriores
- MONTANERA GESTION SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cid De La Paz Garcia Antonio
ORGANIGRAMA DE CIDEPA-SINCRON SL
VINCULACIONES DE CIDEPA-SINCRON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIDEPA-SINCRON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cid De La Paz Garcia Adolfo | Vicesecret. | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Adolfo | Consejero | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Antonio | Presidente | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Antonio | Consejero | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Ines Maria | Consejero Delegado | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Ines Maria | Consejero | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Ismael | Secretario | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Ismael | Consejero | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Ismael | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2015 | |
Cid De La Paz Garcia Jose Manuel | Consejero | 07/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CIDEPA-SINCRON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 16, S 8, H SE 67239, I/A 9 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
- Sociedades absorbidas: SISTEMAS DE LIQUIDOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 12, S 8, H SE 67239, I/A 8 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 12, S 8, H SE 67239, I/A 8 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Capital Anterior: | 2.286.610,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.084,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.296.694,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 12, S 8, H SE 67239, I/A 8 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 11, S 8, H SE 67239, I/A 7 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 159, S 8, H SE 67239, I/A 6 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 159, S 8, H SE 67239, I/A 6 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 159, S 8, H SE 67239, I/A 6 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
- Sociedades absorbidas: REDUME SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 156, S 8, H SE 67239, I/A 5 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Capital.-. 4. Retribución del cargo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4378 , F 156, S 8, H SE 67239, I/A 5 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41