COSTA CALIFORNIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vicente Aleixandre, 3
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COSTA CALIFORNIA SL
CIF B84041508
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/06/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE COSTA CALIFORNIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COSTA CALIFORNIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | Administrador Mancomunado | 26/01/2010 | 08/03/2022 |
Vera Vazquez Francisco | Administrador Concursal | 09/07/2012 | 08/03/2022 |
DESARROLLO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SA EN LIQUIDAC | Administrador Mancomunado | 22/07/2016 | |
FERRIS HILLS SL | Administrador Mancomunado | 26/01/2010 | 22/07/2016 |
Moreno Sainz Pardo Jose Antonio | Representante | 26/01/2010 | 22/07/2016 |
Murcia Vela Andres | Representante | 25/01/2012 | 22/07/2016 |
Murcia Vela Antonio | Representante | 26/01/2010 | 25/01/2012 |
Chica Lucas Juan Diego | Apoderado | 01/02/2010 | |
Cuerda Cabrerizo Fernando | Apoderado | 01/02/2010 | |
Garzas Cejudo Angel | Apoderado | 01/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COSTA CALIFORNIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 208, S 8, H M 356724, I/A 10 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COSTA CALIFORNIA SL
Nif:B84041508
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Vera Vazquez Francisco
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:27/06/2012
Número Procedimiento Concursal:294/2012
Datos Registrales:
Tomo:
20196
Libro:
0
Folio:
208
Hoja:
8-356724
Inscripción:
10
Fecha Inscripción08/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 208, S 8, H M 356724, I/A 10 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COSTA CALIFORNIA SL
Nif:B84041508
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS
Fecha de Resolución:03/02/2022
Número Procedimiento Concursal:294/2012
Datos Registrales:
Tomo:
20196
Libro:
0
Folio:
208
Hoja:
8-356724
Inscripción:
10
Fecha Inscripción08/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 208, S 8, H M 356724, I/A 10 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 207, S 8, H M 356724, I/A B (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COSTA CALIFORNIA SL
Nif:B84041508
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
DURANTE LA FASE DE LIQUIDACION QUEDAN EN SUSPENSO LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL CONCURSADO SOBRE SU PATRIMONIO
Fecha de Resolución:23/06/2016
Número Procedimiento Concursal:294/2012
Datos Registrales:
Tomo:
20196
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-356724
Inscripción:
B
Fecha Inscripción22/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 207, S 8, H M 356724, I/A B (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COSTA CALIFORNIA SL
Nif:B84041508
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
MEDIANTE AUTO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2016, SE ACUERDA LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, QUEDANDO LA SOCIEDAD DISUELTA Y CESADOS SUS ADMINISTRADORES
Fecha de Resolución:23/06/2016
Número Procedimiento Concursal:294/2012
Datos Registrales:
Tomo:
20196
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-356724
Inscripción:
B
Fecha Inscripción22/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 207, S 8, H M 356724, I/A B (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 207, S 8, H M 356724, I/A B (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COSTA CALIFORNIA SL
Nif:B84041508
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vera Vazquez Francisco
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:27/06/2012
Número Procedimiento Concursal:294/2012
Datos Registrales:
Tomo:
20196
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-356724
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/07/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 207, S 8, H M 356724, I/A A (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COSTA CALIFORNIA SL
Nif:B84041508
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:27/06/2012
Número Procedimiento Concursal:294/2012
Datos Registrales:
Tomo:
20196
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-356724
Inscripción:
A
Fecha Inscripción09/07/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 207, S 8, H M 356724, I/A A (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20196 , F 207, S 8, H M 356724, I/A 9 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-28