CYGYC SA - EXTINGUIDA
Municipio Les Franqueses del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CYGYC SA
CIF A08258451
Capital Social 62684.3 Euros
Actividad Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento
Fecha de Constitución 12/11/1970
Página Web www.cygyc.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Grau Durio Jaime
Auditor AUDINFORM SLP
VINCULACIONES DE CYGYC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CYGYC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDINFORM SLP | Auditor | 13/12/2013 | 21/12/2017 |
AUDINFORM SLP | Auditor | 20/12/2016 | 21/12/2017 |
Costa Segu Josep | Secretario | 24/07/2017 | 21/12/2017 |
Costa Segu Josep | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2017 | 21/12/2017 |
Costa Segu Josep | Consejero | 24/07/2017 | 21/12/2017 |
FORTICUS 21 SL | Consejero | 24/07/2017 | 21/12/2017 |
Grau Deprez Andres Francisco | Consejero | 24/07/2017 | 21/12/2017 |
Grau Deprez Daniel | Consejero | 24/07/2017 | 21/12/2017 |
Grau Durio Jaime | Presidente | 24/07/2017 | 21/12/2017 |
Grau Durio Jaime | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2017 | 21/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CYGYC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 204, S 8, H B 49224, I/A 24 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 204, S 8, H B 49224, I/A 24 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 204, S 8, H B 49224, I/A 23 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 204, S 8, H B 49224, I/A 23 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 203, S 8, H B 49224, I/A 22 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 203, S 8, H B 49224, I/A 21 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.6:DOMICILIO.ART.20: ADOPCION DE ACUERDOS. ART.28: REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD. ART.30: RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. ADICION DE LOS ARTICULOS 19 BIS Y 34 BIS. SUPRESION DEL ARTICULO 9 BIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 202, S 8, H B 49224, I/A 20 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Capital Anterior: | 66.771,10 | Euros |
Disminución de capital | 4.086,80 | Euros |
Capital Actual: | 62.684,30 | Euros |
Porcentaje: | 6,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 202, S 8, H B 49224, I/A 20 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 201, S 8, H B 49224, I/A 19 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42553 , F 201, S 8, H B 49224, I/A 19 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-08