DIAGONAL FOOD SL - EXTINGUIDA
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DIAGONAL FOOD SL
CIF B66305095
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/05/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE DIAGONAL FOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIAGONAL FOOD SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Christophe Cizeron | Apoderado Solidario | 10/07/2019 | 31/07/2023 |
| Christophe Regis Guerin | Liquidador | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Christophe Regis Guerin | Consejero Delegado Solidario | 05/09/2022 | 31/07/2023 |
| Christophe Regis Guerin | Presidente | 05/09/2022 | 31/07/2023 |
| Christophe Regis Guerin | Consejero | 05/09/2022 | 31/07/2023 |
| Daniel Georges Jean Chapiro | Consejero Delegado | 11/03/2015 | 31/07/2023 |
| Daniel Georges Jean Chapiro | Consejero | 11/03/2015 | 31/07/2023 |
| Daniel Georges Jean Chapiro | Liquidador | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Eric Rostagnat | Apoderado Solidario | 27/08/2015 | 31/07/2023 |
| FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 26/01/2017 | 31/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIAGONAL FOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 13, S 8, H B 453819, I/A 13 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 13, S 8, H B 453819, I/A 13 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 13, S 8, H B 453819, I/A 13 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 12, S 8, H B 453819, I/A 11 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 12, S 8, H B 453819, I/A 11 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 11, S 8, H B 453819, I/A 10 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 11, S 8, H B 453819, I/A 9 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 11, S 8, H B 453819, I/A 8 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44359 , F 105, S 8, H B 453819, I/A 7 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
- ANULADA LA INSCRIPCION 5 REFERENTE AL CONFERIMIENTO DE PODER A DON MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ Y DON YANN JACQUES MUTEL POR CUANTO LA ESCRITURA EN LA QUE SE FORMALIZO DICHO PODER, QUE MOTIVO LA INS.5 FUE INSCRITA EN ESTE REGISTRO EN LA 4
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44359 , F 105, S 8, H B 453819, I/A 6 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08