DIPALA DIRECTORSHIP SL
Dirección social Calle Ribera del Loira, 28
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DIPALA DIRECTORSHIP SL
CIF B88642087
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/05/2020
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Matesanz Postigo Fermin
ORGANIGRAMA DE DIPALA DIRECTORSHIP SL
VINCULACIONES DE DIPALA DIRECTORSHIP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DIPALA DIRECTORSHIP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badillo Serrano Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2024 | |
Bascones Perez-fragero Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2024 | |
Fernandez Alonso Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2024 | |
Gonzalez Pilar Maria Paz | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2024 | |
Hervas Zurita Montserrat | Apoderado Solidario | 01/03/2024 | |
Hervas Zurita Montserrat | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2024 | |
Justel Miranda Raul | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2024 | |
Martinez Berrocal Celia Maria | Apoderado Solidario | 01/03/2024 | |
Muñoz Redondo Vanesa | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2024 | |
Pascual Velazquez Alfonso | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DIPALA DIRECTORSHIP SL
- Revocadas parcialmente las facultades bancarias del apartado F de la escritura que causó la inscripción 6, en cuanto a los apoderados D.Juan Manuel Abellán Esparcia, D.Miguel Bascones Pérez-Fragero, D.Antonio Badillo Serrano y D.Leopoldo Valle Gutiérrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 39, S 8, H M 719725, I/A 7 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 39, S 8, H M 719725, I/A 7 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Apoderado
- Abellan Esparcia Juan Manuel
- Badillo Serrano Antonio
- Bascones Perez-fragero Miguel
- De La Cruz Martinez Pablo Federico
- Diaz Rodriguez Antonio
- Fernandez Alonso Daniel
- Hervas Zurita Montserrat
- Lopez Serrano Maria De Los Dolores
- Martinez Paris Raul
- Pascual Velazquez Alfonso
- Rodriguez Ascaso Raul De Los Santos
- Santos Montero Miguel Angel
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 36, S 8, H M 719725, I/A 6 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 36, S 8, H M 719725, I/A 5 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 36, S 8, H M 719725, I/A 5 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
- C/ RIBERAL DEL LOIRA 28 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 35, S 8, H M 719725, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
- la promoción, desarrollo, gestión y financiación de proyectos de energía renovable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 34, S 8, H M 719725, I/A 3 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
- C/ MARQUES DE LA ENSENADA 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 34, S 8, H M 719725, I/A 3 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 34, S 8, H M 719725, I/A 3 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40545 , F 34, S 8, H M 719725, I/A 3 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28