ECOSENSES 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Vivanco, 12
Código Postal 12550
Municipio Almassora
Provincia Castellón/Castello
Razón Social ECOSENSES 2 SL
CIF B44510592
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Cultivo de cítricos
Fecha de Constitución 06/08/2018
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Morera Garcia Carlos
Propietario EBRANSAR SL
VINCULACIONES DE ECOSENSES 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECOSENSES 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aroco Belmonte Pedro | Apoderado Solidario | 23/11/2022 | 20/09/2024 |
CITRICO GLOBAL SL | Secretario | 26/12/2018 | 20/09/2024 |
CITRICO GLOBAL SL | Consejero | 26/12/2018 | 20/09/2024 |
Donaire Postigo Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/12/2018 | 20/09/2024 |
EBRANSAR SL | Consejero | 26/12/2018 | 20/09/2024 |
EBRANSAR SL | Socio Unico | 30/08/2018 | 20/09/2024 |
Herrero Silla Pascual | Apoderado Solidario | 23/11/2022 | 20/09/2024 |
Jorques Cañes Francisco Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/12/2018 | 20/09/2024 |
Larios Saura Sergio | Apoderado Mancomunado | 26/12/2018 | 20/09/2024 |
Llorca Llopis Encarna | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/12/2018 | 20/09/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ECOSENSES 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 41363, I/A 8 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-12
- SUBSANADO ERROR MATERIAL EN CUANTO A LAS FACULTADES CONFERIDAS A LOS APODERADOS QUE CONSTAN EN LA INSCRIPCION 5ª, por Diligencia de subsanación de la ESCRITURA de poder otorgada en Valencia, el 10 de noviembre de 2022, ante el citado Notario Sr. Cervera Taulet, número 5484 de su protocolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 70, S 8, H CS 41363, I/A 6 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 70, S 8, H CS 41363, I/A 6 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 57, S 8, H CS 41363, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-12
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, QUE REGULA LA RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 57, S 8, H CS 41363, I/A 4 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 54, S 8, H CS 41363, I/A 3 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 54, S 8, H CS 41363, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-12
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 54, S 8, H CS 41363, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 54, S 8, H CS 41363, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-12
- Dispensa de prohibición de competencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 52, S 8, H CS 41363, I/A 1 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-12