GIMSA MOBEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Matalebreras, S/N
Código Postal 42110
Municipio Ólvega
Provincia Soria
Razón Social GIMSA MOBEL SL
CIF B42169581
Actividad Fabricación de muebles de cocina
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor Huarte Cristobal Marcos
VINCULACIONES DE GIMSA MOBEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIMSA MOBEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
38 2011 ADMINSITRADORES CONCURSALES SL | Liquidador | 30/10/2017 | 30/10/2017 |
Bermejo Arregui Jesus | Auditor Suplente | 24/03/2012 | 30/10/2017 |
Huarte Cristobal Marcos | Auditor | 24/03/2012 | 30/10/2017 |
Sanz De La Fuente Victor Rodrigo | Administrador Solidario | 28/07/2015 | 30/10/2017 |
Sanz De La Fuente Virginia | Administrador Solidario | 28/07/2015 | 30/10/2017 |
De La Fuente Rodrigo Elvira | Consejero | 28/07/2015 | |
Sanz De La Fuente Victor Rodrigo | Consejero Delegado Solidario | 28/07/2015 | |
Sanz De La Fuente Victor Rodrigo | Secretario | 28/07/2015 | |
Sanz De La Fuente Victor Rodrigo | Consejero | 28/07/2015 | |
Sanz De La Fuente Virginia | Consejero Delegado Solidario | 28/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GIMSA MOBEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 7 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-42
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 7 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-42
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 7 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-42
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 7 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-42
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 6 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-42
- Otras modificaciones estatutarias: 11. Funcionamiento Junta Gral.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 6 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-42
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 6 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-42
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 6 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-42
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 52, S 8, H SO 2006, I/A 5 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-42
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134, L 83, F 51, S 8, H SO 2006, I/A 4 (24/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-42