GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
Dirección social AVDA DE LOS PIRINEOS 9 - NAVE 8
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
CIF B86949716
Capital Social 1783000.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 24/02/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Feliu Rius Tomas
ORGANIGRAMA DE GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
VINCULACIONES DE GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vinyoles Millet Jordi | Secretario | 26/02/2025 | |
Vinyoles Millet Jordi | Consejero | 26/02/2025 | |
Cano Esteban Hector | Apoderado | 25/04/2018 | |
Cordero Tosal Fernando Jose | Apoderado | 25/04/2018 | |
De Isabel Garcia Juan Antonio | Apoderado | 25/04/2018 | |
Feliu Garcia Lluis | Apoderado | 25/04/2018 | |
Feliu Rius Tomas | Apoderado | 25/04/2018 | |
Vinyoles Millet Jordi | Apoderado | 25/04/2018 | |
De Isabel Garcia Juan Antonio | Apoderado Mancomunado | 30/04/2015 | |
Del Corral Gargallo Rafael | Apoderado Mancomunado | 30/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GREENMARK MODULAR ARCHITECTURE SL
- AVDA DE LOS PIRINEOS 9 - NAVE 8 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 575204, I/A 10 (28/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-46-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 575204, I/A 9 (26/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-44-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 575204, I/A 9 (26/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-44-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 16 y 17 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 575204, I/A 8 (26/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-44-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 194, S 8, H M 575204, I/A 7 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31960 , F 159, S 8, H M 575204, I/A 6 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
- La intermediación en la dirección, desarrollo, planificación y ejecución de proyectos de todo tipo en especial los de alta eficiencia energética y sostenibilidad, la explotación, montaje, reparación y el asesoramiento empresarial a terceros, todo ello, relativo a todo tipo de hangares, módulos tra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31960 , F 158, S 8, H M 575204, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Capital Anterior: | 783.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.783.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 127,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31960 , F 158, S 8, H M 575204, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 780.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 783.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 26.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31960 , F 157, S 8, H M 575204, I/A 4 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31960 , F 156, S 8, H M 575204, I/A 3 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28