IGENOMIX SL
Dirección social RONDA NARCISO MONTURIOL 11 B - PARQUE TECNOLOGICO
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social IGENOMIX SL
CIF B98112329
Capital Social 65582.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 15/01/2009
Teléfono 96 390 53 10
Página Web www.igenomix.com
Nombres Anteriores
- IVIOMICS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Capella Soriano Ricardo Manuel
Propietario MENDEL BIDCO SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE IGENOMIX SL
VINCULACIONES DE IGENOMIX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IGENOMIX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnau Colomer Belen | Apoderado Solidario | 13/05/2025 | |
Capella Soriano Ricardo Manuel | Apoderado Solidario | 13/05/2025 | |
Frigols Ballester Beatriz | Apoderado Solidario | 13/05/2025 | |
Gomez Salvador Maria Carmen | Apoderado Solidario | 13/05/2025 | |
Gutierrez Martin Guillermo | Secretario No Consejero | 13/05/2025 | |
Leon Roig Vicente | Consejero | 13/05/2025 | |
Leon Roig Vicente | Apoderado Solidario | 13/05/2025 | |
O'connor Bronwyn Anne | Apoderado Solidario | 13/05/2025 | |
Perez Blasco Alexis | Apoderado Solidario | 13/05/2025 | |
Perez Lloret Rosa Maria | Apoderado Solidario | 13/05/2025 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IGENOMIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 133171, I/A 49 (13/05/2025)
CVE: BORME-A-2025-94-46
Apoderado Solidario
- Arnau Colomer Belen
- Capella Soriano Ricardo Manuel
- Ferrando Huertas Guillermo
- Ferrando Huertas Guillermo
- Gomez Salvador Maria Carmen
- Gomez Salvador Maria Del Carmen
- Lara Pino Lucia
- Perez Lloret Rosa Maria
- Piñeiro Iglesias Jose Ignacio
- Riera Magraner Ana
- Risberg Lars
- Soria Gallardo Cristina
- Tolf Patrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 133171, I/A 49 (13/05/2025)
CVE: BORME-A-2025-94-46
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 133171, I/A 48 (13/05/2025)
CVE: BORME-A-2025-94-46
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 133171, I/A 48 (13/05/2025)
CVE: BORME-A-2025-94-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 133171, I/A 47 (06/05/2025)
CVE: BORME-A-2025-89-46
- Sociedades absorbidas: MENDEL HOLDCO SL
- Sociedades absorbidas: MENDEL BIDCO SL
- Sociedades absorbidas: NEW GENETICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 133171, I/A 46 (14/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-13-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10687, L 7968, F 149, S 8, H V 133171, I/A 44 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10687, L 7968, F 20, S 8, H V 133171, I/A 43 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10687, L 7968, F 20, S 8, H V 133171, I/A 43 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 25..- Cargos del Consejo de Administración. 25.1. Si se optase por Consejo de Administración, este designará a su Presidente y Secretario. Se podrán nombrar también uno o varios Vicesecretarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10687, L 7968, F 19, S 8, H V 133171, I/A 42 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46