JGP SL
Dirección social CL ORIENTE 78-84 EDIFICIO INBISA,1 PLA.DESPACHO Nu
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social JGP SL
CIF B58604893
Capital Social 746145.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Teléfono 93 544 23 87
Nombres Anteriores
- JGP SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Guimil Dominguez Julio
ORGANIGRAMA DE JGP SL
VINCULACIONES DE JGP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JGP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guimil Parra Juan | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2020 | |
Guimil Parra Juan | Consejero | 13/02/2020 | |
Guimil Dominguez Julio | Presidente | 26/07/2016 | |
Guimil Dominguez Julio | Consejero | 26/07/2016 | |
Guimil Parra Ana | Secretario | 26/07/2016 | |
Guimil Parra Ana | Consejero | 26/07/2016 | |
Guimil Parra Maria Luisa | Consejero | 26/07/2016 | |
Guimil Parra Marta Colombina | Consejero | 26/07/2016 | |
Parra Muro Maria Luisa | Vicepresidente | 26/07/2016 | |
Parra Muro Maria Luisa | Consejero | 26/07/2016 |
ACTOS BORME DE JGP SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46006 , F 171, S 8, H B 78533, I/A 20 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46006 , F 171, S 8, H B 78533, I/A 19 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46006 , F 171, S 8, H B 78533, I/A 19 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4 Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. MODIFICACION DEL PLAZO DE FINALIZACION DE LAS OPERACIONES SOCIALES. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33791 , F 80, S 8, H B 78533, I/A 18 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33791 , F 80, S 8, H B 78533, I/A 18 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33791 , F 80, S 8, H B 78533, I/A 18 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
- Sociedades absorbidas: MS MOBILIARIO OFICINA SA
- Sociedades absorbidas: SOLITEC CONSULTING SL
- Sociedades absorbidas: NOVA BARCELONA 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33791 , F 77, S 8, H B 78533, I/A 17 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
- (CNAE 6420) PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS PARA,DIRIGIENDOLAS Y GESTIONANDOLAS,DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA SOCIEDAD HOLDING.PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION,DIRECCION Y GERENCIA,ADMINISTRACION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33791 , F 77, S 8, H B 78533, I/A 17 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33791 , F 77, S 8, H B 78533, I/A 17 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES EL DIA 9 DE MAYO DE 2.016. MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD PASANDO A SER DEFINIDO (31/12/2037)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33791 , F 77, S 8, H B 78533, I/A 17 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08