KEBEKA 2002 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KEBEKA 2002 SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sabe Richer Marc
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE KEBEKA 2002 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEBEKA 2002 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/07/2016 | 29/10/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/10/2012 | 29/10/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/08/2009 | 29/10/2019 |
Gil Sanz Raquel | V-SEC NO CON | 17/07/2009 | 29/10/2019 |
Macia Soldevila Carlos | Consejero | 24/05/2016 | 29/10/2019 |
Macia Soldevila Roman Javier | Consejero | 24/05/2016 | 29/10/2019 |
Sabe Richer Jordi Joan | Secretario | 24/05/2016 | 29/10/2019 |
Sabe Richer Jordi Joan | Consejero | 24/05/2016 | 29/10/2019 |
Sabe Richer Marc | Presidente | 24/05/2016 | 29/10/2019 |
Sabe Richer Marc | Consejero | 24/05/2016 | 29/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KEBEKA 2002 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 81, S 8, H M 678413, I/A 3 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
- BAJA DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, POR RESOLUCION DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 81, S 8, H M 678413, I/A 3 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
- CIERRE PROVISIONAL de la hoja de la sociedad por un plazo de SEIS MESES por haber sido absorbida por la sociedad luxemburguesa "AVALORN SICAV, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 80, S 8, H M 678413, I/A 2/M (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
- SE HA INSERTADO CON FECHA 26/11/2018 EN LA PAGINA WEIB WWW.CREDIT- SUISSE.COM/ES/ES/PRIVATE-BANKING/SERVICES/MANAGEMENT.HTML, DE LA SOCIEDAD CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA, ENTIDAD GESTORA DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, EL PROYECTO COMUN DE FUSION POR ABSORCION DE CHERSA 2001 SICAV SA, POR LA SOCIEDAD AVALORN SICAV.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 64, S 8, H M 678413, I/A 1M (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
- C/ AYALA Nº 42, 5ª PLANTA-A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38122 , F 80, S 8, H M 678413, I/A 2 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44857 , F 151, S 8, H B 262987, I/A 20 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-08
- AUTORIZAR A LOS CONSEJEROS A DESEMPEÑAR,POR CUENTA PROPIA O AJENA,CARGOS U OSTENTAR PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA EN SOCIEDADES CON EL MISMO,ANALOGO O COMPLEMENTARIO GENERO DE ACTIVIDAD AL DE LA SOCIEDAD,GESTIONADAS POR UNA "S.G.I.I.C."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44857 , F 151, S 8, H B 262987, I/A 19 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44857 , F 151, S 8, H B 262987, I/A 19 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44857 , F 151, S 8, H B 262987, I/A 19 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. REMUNERACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44857 , F 151, S 8, H B 262987, I/A 18 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08