NUEVA SOCIEDAD DE AGUAS DE IBIZA SA
Razón Social NUEVA SOCIEDAD DE AGUAS DE IBIZA SA
CIF A07043425
Actividad Captación, depuración y distribución de agua
Teléfono 97 131 38 11
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Matutes Prats Abel
ORGANIGRAMA DE NUEVA SOCIEDAD DE AGUAS DE IBIZA SA
VINCULACIONES DE NUEVA SOCIEDAD DE AGUAS DE IBIZA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVA SOCIEDAD DE AGUAS DE IBIZA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortiz De Montellano Garcia Salvador | Apoderado Mancomunado | 25/06/2024 | |
Serra Tur Antonio Vicente | Apoderado Mancomunado | 25/06/2024 | |
Vidal Valls Pere | Apoderado Mancomunado | 25/06/2024 | |
Matutes Prats Abel | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2023 | |
Matutes Prats Abel | Presidente | 30/01/2023 | |
Matutes Prats Maria Del Carmen | Secretario | 30/01/2023 | |
Matutes Prats Maria Del Carmen | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2023 | |
Matutes Prats Maria Del Carmen | Consejero | 22/11/2018 | |
TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS SA | Consejero | 22/11/2018 | |
Matutes Prats Abel | Consejero | 08/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVA SOCIEDAD DE AGUAS DE IBIZA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IB 2014, I/A 15 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-07
- Sustituido el representante persona física de la Consejera de la sociedad TRATAMIENTO INDUSTRAL DE AGUAS SA, de DON PEDRO PUGIDENGOLES BRIONES, por DON LUIS LPOEZ BARRERA, con DNI 46951060X
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391, L 389, F 172, S 8, H IB 2014, I/A 14 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-07
- Designado don Juan Luis Castillo Castilla con D.N.I. 39.683.280-T como persona física representante de SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA, S.I.A., S.A.U., y don Pedro Puigdengoles Briones con D.N.I. 38.137.200-A como persona física representante de TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS, S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41, L 41, F 194, S 8, H IB 2014, I/A 13 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-07
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41, L 41, F 194, S 8, H IB 2014, I/A 13 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-07
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41, L 41, F 194, S 8, H IB 2014, I/A 13 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41, L 41, F 194, S 8, H IB 2014, I/A 13 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41, L 41, F 193, S 8, H IB 2014, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41, L 41, F 193, S 8, H IB 2014, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41, L 41, F 193, S 8, H IB 2014, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-07
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el art. 21 de los estatutos sociales en lo referente a la retribucion del organo de administracion.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41, L 41, F 193, S 8, H IB 2014, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-07