PLATAFORMA AEPROSER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 51
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLATAFORMA AEPROSER SL
CIF B86116456
Capital Social 1336906.0 Euros
Fecha de Constitución 15/12/2010
Nombres Anteriores
- PLATAFORMA AEPROSER SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PLATAFORMA AEPROSER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLATAFORMA AEPROSER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Maceiras Julio Marcos | Liquidador | 23/11/2018 | 23/11/2018 |
Garcia Maceiras Julio Marcos | Apoderado | 12/07/2011 | 23/11/2018 |
Julio Marcos Garcia Maceiras | Administrador Unico | 11/09/2017 | 23/11/2018 |
Sellares Esmarats Jose Maria | Consejero | 19/05/2011 | 23/11/2018 |
ANDALUZA DE TRAMITACIONES Y GESTIONES SA | Consejero | 19/05/2011 | 11/09/2017 |
Bellver Gabana Santiago | Presidente | 19/05/2011 | 11/09/2017 |
Bellver Gabana Santiago | Consejero | 19/05/2011 | 11/09/2017 |
De La Calle Gonzalez Nuria | Representante | 19/05/2011 | 11/09/2017 |
Garcia Maceiras Julio Marcos | Secretario | 19/05/2011 | 11/09/2017 |
Garcia Maceiras Julio Marcos | Consejero | 19/05/2011 | 11/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLATAFORMA AEPROSER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 143, S 8, H M 513742, I/A 11 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 143, S 8, H M 513742, I/A 11 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 143, S 8, H M 513742, I/A 11 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 143, S 8, H M 513742, I/A 11 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28537 , F 115, S 8, H M 513742, I/A 10 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28537 , F 115, S 8, H M 513742, I/A 10 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Consejero
- ANDALUZA DE TRAMITACIONES Y GESTIONES SA
- Bellver Gabana Santiago
- Garcia Maceiras Julio Marcos
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- Massot Felip Xavier
- Menendez Moran Reverte Ignacio
- Peñalver De La Calle Jose Maria
- PONS CONSULTORES REGISTRALES SA
- Sellares Esmarats Josep Maria
- TECNITASA GESTION HIPOTECARIA SA
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28537 , F 115, S 8, H M 513742, I/A 10 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28537 , F 115, S 8, H M 513742, I/A 9 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28537 , F 115, S 8, H M 513742, I/A 9 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-28
Capital Anterior: | 990.280,00 | Euros |
Aumento de capital: | 346.626,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.336.906,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28537 , F 111, S 8, H M 513742, I/A 8 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-28