SIGNIFER SL
Dirección social Calle Segre, 29
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIGNIFER SL
CIF B75728782
Capital Social 90.0 Euros
Fecha de Constitución 24/12/2024
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Girelli Alfredo Juan
ORGANIGRAMA DE SIGNIFER SL
VINCULACIONES DE SIGNIFER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIGNIFER SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Guardia Alba Maria Jesus | Apoderado Solidario | 15/07/2025 | |
| Nannini Beverly Jean | Apoderado Solidario | 15/07/2025 | |
| BLUE ZONE LONGEVITY SL | Consejero | 04/07/2025 | |
| BLUE ZONE LONGEVITY SL | Secretario | 04/07/2025 | |
| De La Peña Alonso-araujo Manuel | Representante | 04/07/2025 | |
| Girelli Alfredo Juan | Presidente | 04/07/2025 | |
| Girelli Alfredo Juan | Consejero | 04/07/2025 | |
| Gonzalez Villate Alvaro | Consejero | 04/07/2025 | |
| Gonzalez Villate Alvaro | Vicepresidente | 04/07/2025 | |
| Gonzalez Villate Alvaro | Apoderado | 08/04/2025 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIGNIFER SL
- a) Fabricación de productos farmacéuticos de base, producción biotecnológica, fabricación de probiéticos. CNAE 2110. b) Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. (no clasificados en otras partes), suplementos alimenticios o nutracéuticos. CNAE 1089. c) Compra y venta de acciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 6 (02/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-6-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 5 (15/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-138-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. SE MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, QUE PASA A SER DE 0,10 -, E IGUALMENTE SE CREAN DESPUES DEL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO, LA CREACION DE DOS TIPOS DE CLASES DE PARTICIPACIONES SOCIALES: CLASE A Y CLASE B
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 4 (04/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-131-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 5º, 8º, 9º, 11º Y 15º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 4 (04/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-131-28
| Capital Anterior: | 1,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 89,00 | Euros |
| Capital Actual: | 90,00 | Euros |
| Porcentaje: | 8.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 4 (04/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-131-28
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 4 (04/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 4 (04/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-131-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 4 (04/07/2025)
CVE: BORME-A-2025-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 3 (08/04/2025)
CVE: BORME-A-2025-73-28
- Se publicó por error en la constitución el nombramiento como administrador único y socio único de MACIAN MARTINEZ MARIA siendo lo correcto GIRELLI ALFREDO JUAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 843928, I/A 1 (24/01/2025)
CVE: BORME-A-2025-33-28