SISTEMA INTEGRAL DE COMPRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Quart, 104
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SISTEMA INTEGRAL DE COMPRAS SL
CIF B98588734
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 25/11/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SISTEMA INTEGRAL DE COMPRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SISTEMA INTEGRAL DE COMPRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillen Gorbe Tomas | Administrador Unico | 04/06/2018 | 27/01/2022 |
Guillen Gorbe Tomas | Liquidador Unico | 27/01/2022 | 27/01/2022 |
De Yarza Lopez-madrazo Iñigo | Consejero | 19/12/2013 | 04/06/2018 |
Guillen Gorbe Tomas | Presidente | 19/12/2013 | 04/06/2018 |
Guillen Gorbe Tomas | Consejero Delegado | 19/12/2013 | 04/06/2018 |
Guillen Gorbe Tomas | Consejero | 19/12/2013 | 04/06/2018 |
Lopez Navarro Sergio | Secretario | 19/12/2013 | 04/06/2018 |
Lopez Navarro Sergio | Consejero | 19/12/2013 | 04/06/2018 |
Mor Vila David | Consejero | 19/12/2013 | 04/06/2018 |
Orti Tarazona Salvador | Consejero | 19/12/2013 | 04/06/2018 |
ACTOS BORME DE SISTEMA INTEGRAL DE COMPRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 4 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 4 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 4 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 4 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 4 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 3 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 3 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 3 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-46
- Dada una nueva redacción íntegra al artículo 13º BIS de los estatutos sociales, al haberse producido error en el mismo en la escritura de constitución
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 79, S 8, H V 157136, I/A 2 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 76, S 8, H V 157136, I/A 1 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-46