SURMEYCA SL - EXTINGUIDA
Municipio San Roque
Provincia Cádiz
Razón Social SURMEYCA SL
CIF B72024789
Fecha de Constitución 14/06/2006
Página Web www.surmeyca.com
Nombres Anteriores
- SURMEYCA SLL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Jeffrey Lawrence Gold
Propietario BEVELLE CAPITAL SL
Auditor Medina Lamadrid Pedro
VINCULACIONES DE SURMEYCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SURMEYCA SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Alexander Jamet | Consejero | 01/09/2023 | 13/01/2026 |
| BEVELLE CAPITAL SL | Socio Unico | 19/10/2023 | 13/01/2026 |
| Gold Jeffrey Lawrence | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2022 | 13/01/2026 |
| Gold Jeffrey Lawrence | Consejero | 17/06/2022 | 13/01/2026 |
| Gold Jeffrey Lawrence | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2022 | 13/01/2026 |
| Jamet Alexander | Consejero | 17/06/2022 | 13/01/2026 |
| Jamet Alexander | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2022 | 13/01/2026 |
| Jeffrey Lawrence Gold | Consejero | 01/09/2023 | 13/01/2026 |
| Jeffrey Lawrence Gold | Presidente | 01/09/2023 | 13/01/2026 |
| Medina Lamadrid Pedro | Auditor | 04/06/2009 | 13/01/2026 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SURMEYCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 32916, I/A 16 (13/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-12-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 32916, I/A 16 (13/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-12-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 32916, I/A 15 (02/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-237-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 155, S 8, H CA 32916, I/A 14 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 154, S 8, H CA 32916, I/A 13 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 32, S 8, H CA 32916, I/A 12 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-11
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 31, S 8, H CA 32916, I/A 11 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 31, S 8, H CA 32916, I/A 11 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 31, S 8, H CA 32916, I/A 10 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 30, S 8, H CA 32916, I/A 9 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11