ERF GARBERA RETAIL SL
Dirección social Calle Principe de Vergara, 112
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ERF GARBERA RETAIL SL
CIF B88001151
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/01/2018
Nombres Anteriores
- TRIBERGLAND SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SL
Propietario CS EUROPEAN RETAIL NO 1 SAL
ORGANIGRAMA DE ERF GARBERA RETAIL SL
VINCULACIONES DE ERF GARBERA RETAIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERF GARBERA RETAIL SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| CS EUROPEAN RETAIL NO 1 SAL | Socio Unico | 07/01/2026 | |
| Pascual Lopez Guillermo | Consejero Delegado Mancomunado | 21/03/2024 | |
| Pascual Lopez Guillermo | Consejero | 21/03/2024 | |
| Orozco Law Richard | Secretario No Consejero | 28/10/2021 | |
| Ramirez De Haro Aguirre Fernando | Representante | 28/10/2021 | |
| SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SL | Presidente | 28/10/2021 | |
| SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SL | Consejero Delegado Mancomunado | 28/10/2021 | |
| SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SL | Consejero | 28/10/2021 | |
| TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 28/10/2021 | |
| Olives Cantalejo David | Vicesecret. | 15/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ERF GARBERA RETAIL SL
- En unión de Escritura de subsanación, extendida, el día 12 de marzo de 2026 por el Notario de Madrid, don Eduardo Avila Rodriguez, por la que dicho Notario, hace constar que la escritura que causó la inscripción 8ª se consignó de forma errónea el protocolo, siendo lo correcto 804/2024
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 661427, I/A 10 (18/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-58-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 661427, I/A 9 (07/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-8-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37023 , F 219, S 8, H M 661427, I/A 8 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37023 , F 219, S 8, H M 661427, I/A 8 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37023 , F 217, S 8, H M 661427, I/A 7 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37023 , F 217, S 8, H M 661427, I/A 7 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37023 , F 217, S 8, H M 661427, I/A 7 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA, 112, PLANTA CUARTA. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37023 , F 105, S 8, H M 661427, I/A 6 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 81, 7ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37023 , F 105, S 8, H M 661427, I/A 5 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS Y CREACION DEL ARTICULO 5 BIS DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37023 , F 105, S 8, H M 661427, I/A 4 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28