UNION DE EMPRESAS GALLEGAS DE AERONAUTICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Vilagarcía de Arousa
Provincia Pontevedra
Razón Social UNION DE EMPRESAS GALLEGAS DE AERONAUTICA SL
CIF B27771534
Capital Social 4014.5 Euros
Fecha de Constitución 25/04/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UNION DE EMPRESAS GALLEGAS DE AERONAUTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION DE EMPRESAS GALLEGAS DE AERONAUTICA SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Alves Diz Carlos | Liquidador | 11/02/2025 | 11/02/2025 |
| DISEÑO E MODELADO DE SUPERFICIES SA | Consejero | 30/05/2017 | 11/02/2025 |
| DISEÑO E MODELADO DE SUPERFICIES SA | Secretario | 30/05/2017 | 11/02/2025 |
| EUROPRECIS GALICIA SL | Consejero | 30/05/2017 | 11/02/2025 |
| Garcia Rodriguez Manuel Jesus | Apoderado | 09/11/2021 | 11/02/2025 |
| Gonzalez Lopez Jesus | Apoderado | 14/06/2012 | 11/02/2025 |
| Gonzalez Silva Jennifer | Secretario | 17/09/2014 | 11/02/2025 |
| THUNE EUREKA SA | Consejero | 30/05/2017 | 11/02/2025 |
| THUNE EUREKA SA | Presidente | 09/11/2021 | 11/02/2025 |
| TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA SA | Consejero | 30/05/2017 | 11/02/2025 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNION DE EMPRESAS GALLEGAS DE AERONAUTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 53263, I/A 16 (11/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-33-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 53263, I/A 16 (11/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-33-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 53263, I/A 16 (11/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-33-36
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 53263, I/A 16 (11/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-33-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 3800, F 128, S 8, H PO 53263, I/A 14 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-36
- POLIG INDUSTRIAL DE BAMIO - RUA PEDROSO 67 (VILAGARCIA DE AROUSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 3800, F 127, S 8, H PO 53263, I/A 13 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-36
- Se acuerda modificar el plazo de duración del nombramiento de los administradores, que pasa a ser indefinido, modificando en consecuencia el artículo 24º de los estatutos sociales.Se modifica el artículo 25º de los estatutos sociales, relativo al Consejo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 3800, F 127, S 8, H PO 53263, I/A 13 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-36
| Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
| Disminución de capital | 985,50 | Euros |
| Capital Actual: | 4.014,50 | Euros |
| Porcentaje: | 19,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 3800, F 127, S 8, H PO 53263, I/A 13 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-36
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 3800, F 127, S 8, H PO 53263, I/A 13 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-36
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800, L 3800, F 127, S 8, H PO 53263, I/A 13 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-36